FURGAL, Rebecca

FURGAL, Rebecca



Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

 1. FURGAL, Rebecca 
   
   
   
   
 2. FURGAL, Michael 
   
   
   
   
   
   
 4. FURGAL, Francis 
 B: 14 Mar 1933 
 P:  New York Mills, Oneida County, New York 
 M: Jan 17 1959 
 P:  St. Mary's Church, Clinton, Oneida County New York 
 D: 27 Jun 2021 
 P:  Utica, Oneida County, New York 
 8. FURGAL, Stanley 
 B: 20 Jul 1912 
 P:  New York Mills, Oneida County, New York, United States of America 
 M:  
 P:   
 D: 15 Jul 1987 
 P:  Utica, Oneida County, New York, United States of America 
 16. FURGAL, John 
   
   
   
   
   
   
 32.  
   
   
   
   
   
   
 33.  
   
   
   
   
 17. FILIPOWICZ, Josephine 
   
   
   
   
 34.  
   
   
   
   
   
   
 35.  
   
   
   
   
 9. UNK, Stella 
   
   
   
   
 18.  
   
   
   
   
   
   
 36.  
   
   
   
   
   
   
 37.  
   
   
   
   
 19.  
   
   
   
   
 38.  
   
   
   
   
   
   
 39.  
   
   
   
   
 5. BRADY, Margaret 
 B: 27 Oct 1937 
 P:  Utica Oneida County New York 
 D: Jan 08 2022 
 P:  St. Luke's Hospital Utica Oneida County New York 
 10. BRADY, Clarence John 
 B: 28 Dec 1910 
 P:  Grenville, Ontario, Canada 
 M: 10 Oct 1933 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 D: 23 May 1956 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 20. BRADY, Philip 
 B: Abt 1874 
 P:  Ontario 
 M:  
 P:   
 D: 29 Nov 1943 
 P:  Utica, Oneida, New York USA 
 40.  
   
   
   
   
   
   
 41.  
   
   
   
   
 21. BURNS, Anna J 
 B: 1884 
 P:  Canada English 
 D:  
 P:   
 42.  
   
   
   
   
   
   
 43.  
   
   
   
   
 11. WELCH, Agnes Bridget 
 B: 16 Sep 1910 
 P:   
 D: 16 Mar 1992 
 P:   
 22. WELCH, Joseph Lawrence 
 B: 28 Nov 1868 
 P:  Sangerfield, Oneida, New York 
 M: 04 Nov 1903 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 D: 16 May 1936 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 44. WELCH, Luke  =>
 B: 1838 
 P:  Galway, Oranmore, Ireland 
 M:  
 P:   
 D: 04 Feb 1918 
 P:  Oneida County, New York, USA 
 45. DONLON, Mary 
 B: Abt 1831 
 P:  Ireland 
 D: Jun 02 1906 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 23. BOGAN, Mary Agnes 
 B: 10 Jun 1873 
 P:  Sangerfield, Oneida, NY 
 D: 23 Dec 1965 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 46. BOGAN, Lawrence  =>
 B: 1848 
 P:  Wexford, Ireland; Lady's Island Parish; Fern Diocese 
 M: 07 Feb 1873 
 P:  Waterville, Oneida County, New York, USA 
 D: 1929 
 P:   
 47. MCCABE, Bridget  =>
 B: 18 Jul 1852 
 P:  Ireland, Wexford 
 D: 02 Feb 1927 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 3. IMHOFF, Deborah Mary 
   
   
   
   
 6. IMHOFF, Richard Joseph 
 B: 04 Jun 1935 
 P:  Utica, Oneida, New York USA 
 M: 28 Nov 1959 
 P:  Saint Mary's Church Clinton New York 
 D: 25 Sep 2023 
 P:  Clayton, North Carolina 
 12. IMHOFF, Walter J 
 B: 03 Jul 1914 
 P:  New York, New York, USA 
 M: 28 Nov 1934 
 P:  St. Joseph's Church; Utica, Oneida County, New York 
 D: 03 Nov 1977 
 P:  Whitesboro, Oneida, New York, United States of America 
 24. IMHOFF, John Frederick 
 B: 05 Dec 1881 
 P:  Utica, Oneida, New York USA 
 M: 21 Jul 1909 
 P:  Whitesboro, Oneida, New York, United States of America 
 D: 29 Jul 1962 
 P:  Whitesboro, Oneida, New York, United States of America 
 48. IMHOFF, Joseph  =>
 B: 26 Sep 1849 
 P:  Oneida, New York, USA 
 M: 12 Jan 1875 
 P:  St. Joseph's Church; Utica, Oneida County, New York 
 D: 18 Feb 1937 
 P:  Utica NY (St. Elizabeth's Hospital) 
 49. GENTZ, Louisa  =>
 B: 21 Feb 1852 
 P:  Saxony, Germany 
 D: 18 Dec 1929 
 P:  Utica, Oneida, New York USA 
 25. LANDRY, Rose L 
 B: 1886 
 P:  Sherbrook, Canada 
 D: 31 Jul 1970 
 P:   
 50. LANDRY, Pascal  =>
 A: 1839 
 P:  L`Acadie, Québec (Quebec) 
 M: 1874 
 P:   
 D:  
 P:   
 51. FOURNIER, Marance  =>
 B: Aug 1843 
 P:  Canada French 
 D: 20 Nov 1922 
 P:  Varick Street Utica New York 
 13. CAHOW, Evelyn C 
 B: 18 Apr 1916 
 P:  Marcy, New York 
 D: 03 Nov 1977 
 P:  Marcy, New York 
 26. CAHOW, Raymond Richard 
 B: 07 Dec 1883 
 P:  Mt. Pleasant, Isabella, Michigan, USA 
 M: 22 Jul 1906 
 P:  Thorice Michigan 
 D: 13 May 1961 
 P:  Nyack,Rockland Co.,NY 
 52. CAHOW, William Ransom  =>
 B: 15 Nov 1858 
 P:  Akron,Summit Co.,OH 
 M: 10 Jul 1873 
 P:  Toledo,Lucas Co.,OH 
 D: 10 Nov 1928 
 P:  Newberry, Luce, Michigan, USA 
 53. STOYLE, Henrietta Victoria  =>
 B: 22 Feb 1853 
 P:  Cramma, Hastings, Ontario, Canada 
 D: 13 Apr 1925 
 P:  Oak Ridge Park, Chippewa, Michigan, USA 
 27. LONGHURST, Violet MARY 
 B: Jul 1888 
 P:  Sault St Marie, Michigan 
 D: 05 Oct 1941 
 P:  Rome, Oneida, New York, United States Of America 
 54. LONGHURST, John  =>
 B: 16 Feb 1842 
 P:  Mulmur Township, Simcoe, Ontario, Canada 
 M: 25 Dec 1865 
 P:  Mulmur Township, Simcoe, Ontario, Canada 
 D: 7 Aug 1917 
 P:  Sault St Marie, Michigan 
 55. WHITLEY, Ann  =>
 B: 1848 
 P:  Mulmur Township, Simcoe, Ontario, Canada 
 D:  
 P:  Sault St Marie, Michigan 
 7. PRYOR, Anne Marie 
 B: 10 Mar 1938 
 P:  Utica, Oneida, New York USA 
 D: 14 Sep 2002 
 P:  Verona, Oneida, New York, United States of America 
 14. PRYOR, James Houston 
 B: 05 Apr 1907 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 M: 28 Oct 1936 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 D: 28 Jan 1995 
 P:  Floyd Avenue, Rome New York 
 28. PRYOR, Daniel Henry 
 B: 20 Apr 1872 
 P:  Westmoreland, Oneida, New York, United States 
 M: 31 Oct 1900 
 P:  Saint Mary's Church Clinton New York 
 D: 15 Sep 1953 
 P:  Kirkland Iron Works, Kirkland, Oneida County, New York 
 56. PRYOR, James Daniel  =>
 B: 16 Mar 1830 
 P:  Ireland 
 M: 08 Jan 1853 
 P:  Saint Mary's Church Clinton New York 
 D: 16 Oct 1921 
 P:  Kirkland Iron Works, Kirkland, Oneida County, New York 
 57. ROBINSON, Margaret 
 B: 1833 
 P:  Ireland 
 D: 1898 
 P:  Kirkland Iron Works, Kirkland, Oneida County, New York 
 29. QUINN, Marcella Bridget 
 B: 15 Jan 1875 
 P:  Kirkland Iron Works, Kirkland, Oneida County, New York 
 D: 13 Jan 1959 
 P:  Kirkland Iron Works, Kirkland, Oneida County, New York 
 58. QUINN, Thomas Foran  =>
 B: Abt 1845 
 P:   
 M:  
 P:   
 D: 1919 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 59. HOUSTON, Alice  =>
 B: 19 Aug 1853 
 P:   
 D: 1933 
 P:   
 15. WELCH, Lorretta Mary 
 B: 19 Jan 1907 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 D: 03 Apr 1964 
 P:  Utica NY (St. Luke's Hospital) 
 30. WELCH, Joseph Lawrence 
 B: 28 Nov 1868 
 P:  Sangerfield, Oneida, New York 
 M: 04 Nov 1903 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 D: 16 May 1936 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 60. WELCH, Luke  =>
 B: 1838 
 P:  Galway, Oranmore, Ireland 
 M:  
 P:   
 D: 04 Feb 1918 
 P:  Oneida County, New York, USA 
 61. DONLON, Mary 
 B: Abt 1831 
 P:  Ireland 
 D: Jun 02 1906 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 31. BOGAN, Mary Agnes 
 B: 10 Jun 1873 
 P:  Sangerfield, Oneida, NY 
 D: 23 Dec 1965 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 62. BOGAN, Lawrence  =>
 B: 1848 
 P:  Wexford, Ireland; Lady's Island Parish; Fern Diocese 
 M: 07 Feb 1873 
 P:  Waterville, Oneida County, New York, USA 
 D: 1929 
 P:   
 63. MCCABE, Bridget  =>
 B: 18 Jul 1852 
 P:  Ireland, Wexford 
 D: 02 Feb 1927 
 P:  Clinton, Oneida County, New York